Drucken Lesezeichen hinzufügen

New York, New York County, New York, USA



 

Geographische Breite: 40.712800, Geographische Länge: 74.005800



Geburt

Treffer 1 bis 27 von 27

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 Abrams, William  17 Nov 1910New York, New York County, New York, USA I296398
2 Arden, Agnes  1885New York, New York County, New York, USA I206606
3 Blatt, Gustav Hermann  16 Jun 1883New York, New York County, New York, USA I248054
4 Boehnke, Charles E.  10 Jul 1894New York, New York County, New York, USA I213852
5 Brown, Colleen G.  10 Jun 1930New York, New York County, New York, USA I92850
6 Calzetta, John Joseph  10 Mai 1919New York, New York County, New York, USA I186206
7 Cornwall, Charles A.  11 Jan 1869New York, New York County, New York, USA I224682
8 Drawert, Elsie  um 1908New York, New York County, New York, USA I225429
9 Drawert, Emily  um 1910New York, New York County, New York, USA I225430
10 Drawert, Frederick John  06 Mrz 1900New York, New York County, New York, USA I225428
11 Drawert, Selma  um 1902New York, New York County, New York, USA I225431
12 Erhardt, Richard  12 Mai 1916New York, New York County, New York, USA I92344
13 Evans, Ruth Eleanor  22 Apr 1906New York, New York County, New York, USA I226841
14 Glücksmann, Amalie  01 Dez 1891New York, New York County, New York, USA I223966
15 Herman, Harry S.  um 1869New York, New York County, New York, USA I249880
16 Herzberg, Anna  um 1890New York, New York County, New York, USA I355334
17 Krüger, Augustin Friedrich  10 Jul 1904New York, New York County, New York, USA I286795
18 Martin, Arthur  um 1890New York, New York County, New York, USA I192072
19 O'Brien, John L.  19 Dez 1896New York, New York County, New York, USA I205070
20 Randell, Lee R.  um 1892New York, New York County, New York, USA I195020
21 Ranft, Edward Bernhard  23 Apr 1900New York, New York County, New York, USA I244659
22 Ranft, Edward T.  25 Jan 1925New York, New York County, New York, USA I244662
23 Rillie, Archie C.  11 Dez 1884New York, New York County, New York, USA I29008
24 Solomonic, William  24 Mai 1929New York, New York County, New York, USA I310137
25 Weidhorn, Arthur  26 Jul 1879New York, New York County, New York, USA I63362
26 Westra, Bertha  30 Okt 1923New York, New York County, New York, USA I214381
27 Yobs, Lena  14 Jun 1887New York, New York County, New York, USA I187724

Tod

Treffer 1 bis 12 von 12

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung 
1 Aschemann  New York, New York County, New York, USA I345848
2 Bartsch, Martha Helene Louise  23 Jan 1911New York, New York County, New York, USA I185339
3 Foth, Arthur  21 Feb 1913New York, New York County, New York, USA I118753
4 Gruß, Gudula Ellen  30 Apr 1995New York, New York County, New York, USA I353950
5 Hildebrandt, Scott Jeffrey  14 Mrz 1991New York, New York County, New York, USA I196168
6 Horst, Esther Amelia  Apr 1985New York, New York County, New York, USA I310121
7 Krüger, Augustin  vor 1926New York, New York County, New York, USA I286793
8 Lange, Emilie  vor 1930New York, New York County, New York, USA I122206
9 Nimmergut, Emilie  vor 1926New York, New York County, New York, USA I286794
10 Ranft, Bernhard  09 Dez 1904New York, New York County, New York, USA I244658
11 Rosenberg, Dr. med. Herbert  01 Sep 1954New York, New York County, New York, USA I345847
12 Zerull, Adolph  25 Apr 1965New York, New York County, New York, USA I152246

Beerdigung

Treffer 1 bis 2 von 2

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung 
1 Czepek, Pauline  15 Feb 1898New York, New York County, New York, USA I108372
2 Klafft, August  20 Dez 1888New York, New York County, New York, USA I90571

Eheschließung

Treffer 1 bis 10 von 10

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung 
1 /   06 Jun 1953New York, New York County, New York, USA F18291
2 /   15 Nov 1991New York, New York County, New York, USA F38544
3 /   24 Feb 1996New York, New York County, New York, USA F17565
4 Brien / Koch  14 Apr 1895New York, New York County, New York, USA F87766
5 Drawert / Lange  um 1894New York, New York County, New York, USA F69239
6 Hein / Engel  11 Aug 1895New York, New York County, New York, USA F81979
7 Riemer / Wentzel  11 Okt 1885New York, New York County, New York, USA F64959
8 Schmitz / Gruß  10 Mrz 1961New York, New York County, New York, USA F112490
9 Tiemann / Johnson  18 Jul 1927New York, New York County, New York, USA F63034
10 Wessel / Reincke  24 Jun 1919New York, New York County, New York, USA F60181

Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Betreut von Hans-Jürgen Wolf.

Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.